-
-
Flowserve Control Valves GmbH - Kasernengasse 6, 9500, Villach, AUT, Austria
Company Information
- Company registration number
- 128945a
- Company Status
- LIVE
- Country
- Austria
- Registered Address
- Kasernengasse 6
- 9500
- Villach
- AUT Kasernengasse 6, 9500, Villach, AUT AT
Management
- Managing Directors
-
Jorge Labian Perez (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Altebergengasse 2E/3/2, 1140, Wien, AUT -
Shakeeb Uddin Mir (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
5212 North O'Connor BlvdSuite 700, Irving, Texas 75039, USA -
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens-Uwe Strunk (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Josselinstraße 47, 55232 Alzey, DEU
- Signatory Rights
- Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäfts- führer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis.
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 1920-08-25
- Age Of Company 1920-08-25 105 years
Ownership
- Shareholders
- Flowserve B.V. (GESELLSCHAFTER/IN, 25000000 ATS, 100%) Parallelweg 6 4878 AH Etten-Leur NLD
- Share Capital
- 25000000 ATS
- Paidup Capital
- 25000000
Jurisdiction Particularities
- Company Name (english)
- FLOWSERVE (Austria) GmbH
- Additional Status Details
- Active
- -
- -
- Court
- Handelsgericht Wien
- Previous Names
- Worthington Gesellschaft m.b.H.
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 549300UYP1FIMNVSL792
- VAT Number
- ATU19096500
- Identnumber
- 50458
- Phone
- 02236 315 30
-
Flowserve Control Valves GmbH Company Description
- 02236 315 30 .
Get Flowserve Control Valves GmbH Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870
You are here: Flowserve Control Valves Gmbh - Kasernengasse 6, 9500, Villach, AUT, Austria
- 1920-08-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Firmenbuch
- 2025-10-23 Modification
- Die Firma mit der offiziellen Registernummer *a hat einen neuen Antrag gestellt, eine Änderung in der Gesellschafterstruktur bekannt gemacht und hat eine Unterschriftenprobe zu Vergleichszwecken eingereicht (Musterzeichnung). Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
-
Flowserve Control Valves GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for Flowserve Control Valves GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Annual Accounts
Financial data for the last reported full year
Articles of Association
Founding documents
Credit Report by KSV1870
Official credit data
Credit Check by KSV1870
Brief credit details
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2025
-
2025-10-02 - Musterzeichnung
-
2025-09-22 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2025-10-02 - Antrag
-
2025-09-30 - Antrag
-
2025-09-22 - Verschmelzungsvertrag
-
2025-09-22 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2025-10-15 - Ergänzungsantrag
-
2025-09-30 - Ergänzungsantrag
-
2025-09-22 - Antrag
-
2025-07-03 - Antrag
-
2025-01-27 - Antrag
keyboard_arrow_right 2024
-
2024-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2024-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2024-12-31 - Lagebericht
keyboard_arrow_right 2023
-
2023-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
keyboard_arrow_right 2022
-
2022-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2022-04-08 - Antrag
-
2022-02-08 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2022-02-21 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2022-01-12 - Antrag
keyboard_arrow_right 2021
-
2021-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2021-10-19 - Musterzeichnung
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-10-06 - Musterzeichnung
-
2020-10-06 - Antrag
-
2020-09-03 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2020-01-21 - Protokoll d. Generalversammlung
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-12-31 - Jahresabschluss berichtigt
-
2019-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2017-11-02 - Beschluss d. Gesellschafter
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-12-31 - Lagebericht
-
2016-11-30 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2016-11-30 - Antrag
-
2016-11-30 - Musterzeichnung
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2015-11-04 - Beschluss d. Gesellschafter
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-09-30 - Antrag
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2013-05-23 - Musterzeichnung
-
2013-04-24 - Antrag
-
2013-04-25 - Beschluss d. Gesellschafter
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-08-17 - Antrag
-
2011-08-11 - Antrag
-
2011-08-10 - Antrag
-
2011-06-29 - Spaltungs- und Übernahmsvertrag
-
2011-08-10 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2011-08-03 - Bericht
-
2011-11-30 - Antrag
-
2011-11-17 - Rücktrittserklärung
-
2011-11-24 - Rücktrittserklärung
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2010-08-25 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2010-08-25 - Verschmelzungsvertrag
-
2010-07-14 - Antrag
-
2010-07-22 - Ergänzungsantrag
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2009-07-01 - Musterzeichnung
-
2009-07-01 - Antrag
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2008-10-31 - Antrag
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-01-23 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2007-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2007-04-13 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2007-02-08 - Musterzeichnung
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
keyboard_arrow_right 2005
-
2005-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2005-08-17 - Ergebnisverwendungsbeschluss